Emplacements des bureaux
New Era Technology possède des bureaux dans le monde entier en Asie-Pacifique, aux Amériques, au Royaume-Uni et en Europe.
20,000+
Clients estimés
80+
Bureaux dans le monde
4,500+
Employés

Amériques
Canada
1430 Boulevard
Saint-Martin Ouest,
Laval, QC H7S 1M9,
Canada
Saint-Martin Ouest,
Laval, QC H7S 1M9,
Canada
229 Yonge Street
Suite 400,
Toronto, M5B 1N9
Canada
Suite 400,
Toronto, M5B 1N9
Canada
États-Unis
4695 Chabot Dr.
Suite 102 Pleasanton,
CA 94588,
États-Unis
Suite 102 Pleasanton,
CA 94588,
États-Unis
11450 Knott Street,
Garden Grove,
CA 92841,
États-Unis
Garden Grove,
CA 92841,
États-Unis
7 Progress Drive
Cromwell,
CT 06416,
États-Unis
Cromwell,
CT 06416,
États-Unis
4631 Woodland Corporate Blvd.
Suite 101 Tampa,
FL 33614,
États-Unis
Suite 101 Tampa,
FL 33614,
États-Unis
901 Warrenville Road,
UNIT 210, Lisele,
IL 60532,
États-Unis
UNIT 210, Lisele,
IL 60532,
États-Unis
7506 Honeywell Drive,
Fort Wayne,
IN 46825,
États-Unis
Fort Wayne,
IN 46825,
États-Unis
8940 Vincennes Circle,
Indianapolis,
IN 46268,
États-Unis
Indianapolis,
IN 46268,
États-Unis
13565 McKinley Highway
Suite 4 Mishawaka,
IN 46545,
États-Unis
Suite 4 Mishawaka,
IN 46545,
États-Unis
301 Pennsylvania
Parkway Carmel,
IN 46280,
États-Unis
Parkway Carmel,
IN 46280,
États-Unis
3209 Union Pike,
Richmond,
IN 47374,
États-Unis
Richmond,
IN 47374,
États-Unis
2 Batterymarch Park
Suite 401 Quincy,
MA 02169,
États-Unis
Suite 401 Quincy,
MA 02169,
États-Unis
1405 Xenium Lane N.,
Suite 120, Plymouth,
MN 55441,
États-Unis
Suite 120, Plymouth,
MN 55441,
États-Unis
5929 Baker Road
Suite 475 Minnetonka,
MN 55345,
États-Unis
Suite 475 Minnetonka,
MN 55345,
États-Unis
3530 Toringdon Way,
404, Charlotte,
NC 28277,
États-Unis
404, Charlotte,
NC 28277,
États-Unis
111 Maplewood Avenue
Portsmouth,
NH 03801,
États-Unis
Portsmouth,
NH 03801,
États-Unis
111 Moonachie Avenue
Unit 6 Caesar Place Moonachie,
NJ 07074,
États-Unis
Unit 6 Caesar Place Moonachie,
NJ 07074,
États-Unis
926 Bloomfield Avenue
Glen Ridge
NJ 07028,
États-Unis
Glen Ridge
NJ 07028,
États-Unis
24 Commerce Street,
800/900 Newark,
NJ 07102,
États-Unis
800/900 Newark,
NJ 07102,
États-Unis
80 Route 4,
Suite 400, Paramus,
NJ 07652,
États-Unis
Suite 400, Paramus,
NJ 07652,
États-Unis
7255 Bermuda Road,
Suite D, Las Vegas,
NV 89119,
États-Unis
Suite D, Las Vegas,
NV 89119,
États-Unis
2950 Express Drive South
Suite 112, Islandia,
NY 11749,
États-Unis
Suite 112, Islandia,
NY 11749,
États-Unis
1370 Avenue of the Americas
10th Floor New York,
NY 10019,
États-Unis
10th Floor New York,
NY 10019,
États-Unis
8 Slater Street,
Port Chester,
NY 10573,
États-Unis
Port Chester,
NY 10573,
États-Unis
2717 South Arlington Road,
Akron,
OH 44312,
États-Unis
Akron,
OH 44312,
États-Unis
4445 Lake Forest Drive,
440, Cincinnati,
OH 45242,
États-Unis
440, Cincinnati,
OH 45242,
États-Unis
3445 Millennium Court,
Columbus,
OH 43219,
États-Unis
Columbus,
OH 43219,
États-Unis
8940 Lyra Drive 220,
Columbus,
OH 43240,
États-Unis
Columbus,
OH 43240,
États-Unis
1771 Indian Wood Circle,
Maumee,
OH 43537,
États-Unis
Maumee,
OH 43537,
États-Unis
9078 Union Centre Blvd,
Suite 200 West Chester Township,
OH 45069,
États-Unis
Suite 200 West Chester Township,
OH 45069,
États-Unis
20 Erford Road,
Suite 115, Lemoyne,
PA 17043,
États-Unis
Suite 115, Lemoyne,
PA 17043,
États-Unis
208 Carter Drive
West Chester,
PA 19382,
États-Unis
West Chester,
PA 19382,
États-Unis
1155 Phoenixville Pike
Suite 114-115 West Chester,
PA 19380,
États-Unis
Suite 114-115 West Chester,
PA 19380,
États-Unis
3810 Concorde Parkway,
Suite 500 Chantilly,
VA 20151,
États-Unis
Suite 500 Chantilly,
VA 20151,
États-Unis
2201 E Enterprise Avenue
Suite 201 Appleton,
WI 54913,
États-Unis
Suite 201 Appleton,
WI 54913,
États-Unis
210 McClellan St
Suite 100,200, 201, 207, 307, 310
Wausau, WI 54403,
États-Unis
Suite 100,200, 201, 207, 307, 310
Wausau, WI 54403,
États-Unis
10400 West Innovation Drive
Suite 100 Wauwatosa,
WI 53226
États-Unis
Suite 100 Wauwatosa,
WI 53226
États-Unis
152 Erskine Lane,
Scott Depot,
WV 25560
États-Unis
Scott Depot,
WV 25560
États-Unis
Brésil
Avenida Nacoes Unidas, 14401
Condominio Parque da Cidade
Torre Taruma, 6o andar, cj.611 – CEP
São Paulo – SP, 04794-000,
Brésil
Canada
1430 Boulevard
Saint-Martin Ouest,
Laval, QC H7S 1M9,
Canada
Saint-Martin Ouest,
Laval, QC H7S 1M9,
Canada
229 Yonge Street
Suite 400,
Toronto, M5B 1N9
Canada
Suite 400,
Toronto, M5B 1N9
Canada
Royaume-Uni
133 Queens Road
1st Floor Brighton,
BN13WB,
UK
1st Floor Brighton,
BN13WB,
UK
17-23 High Street,
Slough Berkshire
SL11DY,
UK
Slough Berkshire
SL11DY,
UK
L'Europe
Belgium
Imperiastraat 10,
1930 Zaventem,
Belgium
1930 Zaventem,
Belgium
Romania
Bulevardul 21 decembrie 1989,
104, Et. 2,
Cluj-Napoca,
Romania
104, Et. 2,
Cluj-Napoca,
Romania
APAC
Australie
108 King William Street
Level 1, Adelaide
SA 5000
Australie
Level 1, Adelaide
SA 5000
Australie
43-49 Sandgate Road,
Albion,
QLD 4010
Australie
Albion,
QLD 4010
Australie
140 Abernethy Road,
Unit 1 & 2,
Perth,
Australie
Unit 1 & 2,
Perth,
Australie
Camberwell Road
Suite 4/321,
Camberwell
VIC 3124
Australie
Suite 4/321,
Camberwell
VIC 3124
Australie
Highpoint Building 257/259
Central Coast Hwy,
Erina, NSW 2250,
Australie
Central Coast Hwy,
Erina, NSW 2250,
Australie
122 O’Riordan Street
Mascot,
NSW 2020,
Australie
Mascot,
NSW 2020,
Australie
160 Bridge Street
First Floor Suite 3,
Muswellbrook, NSW 2333
Australie
First Floor Suite 3,
Muswellbrook, NSW 2333
Australie
75 Shortland Esplanade,
Suite 1, Newcastle,
NSW 2300,
Australie
Suite 1, Newcastle,
NSW 2300,
Australie
8 Manning Street,
Taree,
NSW 2430,
Australie
Taree,
NSW 2430,
Australie
Chine
444-452 Des Voeux Rd W
Unit A 2/F,
Hong Kong,
Chine
Unit A 2/F,
Hong Kong,
Chine
Inde
Tower B, Suite 1202,
Brigrade Metropolis
Mahadevapura, Village
Bangalore, 560048,
Inde
Brigrade Metropolis
Mahadevapura, Village
Bangalore, 560048,
Inde
3rd Floor,
Microexcel Plaza No. 72,
Bangalore,
560094
Inde
Microexcel Plaza No. 72,
Bangalore,
560094
Inde
8-2-334
6th Floor Road 3
Green Valley,
Hyderabad, 500034,
Inde
6th Floor Road 3
Green Valley,
Hyderabad, 500034,
Inde
NORTH WING,
3 Cube Towers,
Hyderabad,
500084,
Inde
3 Cube Towers,
Hyderabad,
500084,
Inde
SOUTH WING,
3 Cube Towers,
Hyderabad,
500084,
Inde
3 Cube Towers,
Hyderabad,
500084,
Inde
Nouvelle-Zélande
27 Gillies Avenue
4th Floor, Suite 2,
Newmarket, Auckland, 1023
Nouvelle-Zélande
4th Floor, Suite 2,
Newmarket, Auckland, 1023
Nouvelle-Zélande
115 Blenheim Road
Unit 4, Riccarton,
Christchurch, 8041
Nouvelle-Zélande
Unit 4, Riccarton,
Christchurch, 8041
Nouvelle-Zélande
161A Wordsworth Street
Sydenham,
Christchurch, 8023
Nouvelle-Zélande
Sydenham,
Christchurch, 8023
Nouvelle-Zélande
298 Tristram Street,
1st Floor
Hamilton 3204,
Nouvelle-Zélande
1st Floor
Hamilton 3204,
Nouvelle-Zélande
98 Taradale Road,
Unit 4, Onekawa,
Napier, 4110
Nouvelle-Zélande
Unit 4, Onekawa,
Napier, 4110
Nouvelle-Zélande
53 Queen Street,
Ground Floor
Palmerston North 4410
Nouvelle-Zélande
Ground Floor
Palmerston North 4410
Nouvelle-Zélande
204 Thordon Quay
Level 2, Pipitea,
Wellington, 6011
Nouvelle-Zélande
Level 2, Pipitea,
Wellington, 6011
Nouvelle-Zélande
Malaisie
3B-16-03,
Plaza Sentral Jalan
Stesen Sentral 5,
Kuala Lumpur
Malaisie
Plaza Sentral Jalan
Stesen Sentral 5,
Kuala Lumpur
Malaisie
Singapour
Global Convergence,
18 Robinson Road,
Level 15-01,
Singapore 048547
18 Robinson Road,
Level 15-01,
Singapore 048547
Philippines
18/F
Multinational Bancorporation Centre,
6805 Ayala Avenue Makati City,
Philippines 1226
Multinational Bancorporation Centre,
6805 Ayala Avenue Makati City,
Philippines 1226
MENA
Emirats Arabes Unis
Westburry Tower
Business Bay
Dubai, UAE
Business Bay
Dubai, UAE
Centres d'opérations réseau
Centres d'opérations réseau
Boston, MA, United States
Melbourne, Australia
Auckland, New Zealand
Brighton, United Kingdom
Boston, MA, United States
Melbourne, Australia
Auckland, New Zealand
Brighton, United Kingdom
AV Network Operations Center
West Chester, PA, United States
West Chester, PA, United States